Home | What's New | Privacy and Copyright | Contact

Report: Mainers

         Description: This contains a list of everyone on the tree known to have been born in Maine.


Matches 1 to 250 of 277

1 2 Next»

# Last Name, Given Name(s) Birth Date Birth Place Person ID
1 Sarah    Scarborough, Cumberland Co., Maine   I14420 
2 Boothby, Rachel    Scarborough, Cumberland Co., Maine   I1211 
3 Boston, Susanna    York Co., Maine   I6156 
4 Coburn, Alsy A.    East Thomaston, Knox Co., Maine   I13334 
5 Hall, Lewis Jr.    Rockland, Knox Co., Maine   I1320 
6 Jordan, Angie    Westbrook, Cumberland Co., Maine   I1611 
7 Levensaler, Caleb    Thomaston, Knox Co., Maine   I12727 
8 Levensaler, Eliza K.    Thomaston, Knox Co., Maine   I12693 
9 Levensaler, Lydia    Thomaston, Knox Co., Maine   I12728 
10 Libby, Mary    Scarborough, Cumberland Co., Maine   I14386 
11 Libby, Samuel    Scarborough, Cumberland Co., Maine   I14428 
12 McLellan, Rebecca    Brunswick, Cumberland Co., Maine   I14451 
13 Means, Mary    North Yarmouth, Cumberland Co., Maine   I1212 
14 Strout, Mary    Cape Elizabeth, Cumberland Co., Maine   I3252 
15 Trahan, Nicholas    Montreuil-Bellay, Anjou, Maine-et-Loire, France   I2397 
16 Tyler, Phinehas    Thomaston, Knox Co., Maine   I1372 
17 Trahan, Guillaume  Abt 1601  Montreuil-Bellay, Anjou, Maine-et-Loire, France   I2395 
18 Phips, Sir William  1651  Maine   I12807 
19 Phips, Spencer /Bennett  6 Jun 1685  Washington Co., Maine   I6140 
20 Decker, John III  29 Mar 1706/07  Kittery, York Co., Maine   I6142 
21 Decker, Sarah  10 May 1709  Kittery, York Co., Maine   I6136 
22 Decker, Mary  1 Mar 1711  Kittery, York Co., Maine   I6143 
23 Boynton, William  12 Sep 1712  York Co., Maine   I14311 
24 Boynton, John  1718  York Co., Maine   I14313 
25 Boynton, Joshua  17 Oct 1720  York Co., Maine   I14314 
26 McLellan, John  1720  Wells, York Co., Maine   I124 
27 McLellan, Capt. George Sr.  Nov 1725  Wells, York Co., Maine   I107 
28 McLellan, William  21 Nov 1725  Wells, York Co., Maine   I126 
29 Boynton, Caleb  4 Feb 1726  York Co., Maine   I14315 
30 Webster, John  6 Sep 1726  Portland, Cumberland Co., Maine   I13278 
31 Boothby, Samuel  1 Feb 1727  Kittery, York Co., Maine   I13292 
32 McLellan, Sarah  1727  Cape Elizabeth, Cumberland Co., Maine   I3414 
33 Webster, Mary  Abt 1727  Portland, Cumberland Co., Maine   I108 
34 Boothby, Joseph  19 May 1729  Scarborough, Cumberland Co., Maine   I1127 
35 McLellan, Susannah  9 Mar 1731  Portland, Cumberland Co., Maine   I128 
36 McLellan, Capt. Joseph  20 Aug 1732  Portland, Cumberland Co., Maine   I127 
37 McLellan, Abigail  1738  Portland, Cumberland Co., Maine   I3397 
38 McLellan, Deacon James  1738  Portland, Cumberland Co., Maine   I3366 
39 McLellan, Mary  1740  Gorham, Cumberland Co., Maine   I129 
40 Webster, William  Abt 1740  Maine   I13281 
41 McLellan, Capt. Alexander  1742  Gorham, Cumberland Co., Maine   I3226 
42 Elder, Eunice  1745  New Marlborough, York Co., Maine   I3242 
43 McLellan, Capt. Cary  1 May 1745  Gorham, Cumberland Co., Maine   I3227 
44 Miller, John  4 Jan 1745  Cape Elizabeth, Cumberland Co., Maine   I12557 
45 McLellan, Jane  2 Nov 1748  Gorham, Cumberland Co., Maine   I3228 
46 McLellan, Thomas Sr.  Abt 1749  Cape Elizabeth, Cumberland Co., Maine   I105 
47 Coombs, Lieut. Joseph  10 Mar 1752  Brunswick, Cumberland Co., Maine   I2588 
48 Weed, Deacon James  17 Jul 1753  Brunswick, Cumberland Co., Maine   I3425 
49 Dyer, Hanna  1754  Cape Elizabeth, Cumberland Co., Maine   I106 
50 Davis, Hannah  18 Nov 1755  Boothbay, Lincoln Co., Maine   I15774 
51 Gamble, Elizabeth  3 Jun 1755  Thomaston, Knox Co., Maine   I2589 
52 Levensaler, Christina  4 Aug 1755  Waldoboro, Lincoln Co., Maine   I6405 
53 Davis, Israel  9 Oct 1757  Boothbay, Lincoln Co., Maine   I15763 
54 McLellan, Sarah  28 May 1757  Gorham, Cumberland Co., Maine   I1148 
55 Patterson, Jane "Jenny"  Abt 1757  Saco, York Co., Maine   I12558 
56 McLellan, William  7 Jul 1759  Portland, Cumberland Co., Maine   I1149 
57 Levensaler, Maria  17 Nov 1761  Waldoboro, Lincoln Co., Maine   I6406 
58 McLellan, Capt. Joseph Jr.  18 Apr 1762  Portland, Cumberland Co., Maine   I116 
59 Davis, Betty  21 Jul 1763  Boothbay, Lincoln Co., Maine   I15773 
60 Ilsley, Charlotte  25 Jan 1763  Portland, Cumberland Co., Maine   I948 
61 Levensaler, Katerina  8 Jul 1764  Waldoboro, Lincoln Co., Maine   I6407 
62 McLellan, Elizabeth  18 Apr 1764  Gorham, Cumberland Co., Maine   I1161 
63 Levensaler, Peter  11 Feb 1765  Waldoboro, Lincoln Co., Maine   I3305 
64 Proct, George  1765  Waldoboro, Lincoln Co., Maine   I6046 
65 Davis, John Dresser  10 Jun 1766  Boothbay, Lincoln Co., Maine   I15762 
66 Levensaler, Anne Margaretha  30 Sep 1766  Waldoboro, Lincoln Co., Maine   I6408 
67 Levensaler, Mari Catharine  8 Dec 1766  Waldoboro, Lincoln Co., Maine   I12565 
68 McLellan, Stephen  26 Feb 1766  Portland, Cumberland Co., Maine   I115 
69 Stone, Rebecca  1766  Brunswick, Cumberland Co., Maine   I756 
70 Davis, Prudence  10 May 1768  Boothbay, Lincoln Co., Maine   I15771 
71 Levensaler, John Jacob  8 Nov 1768  Waldoboro, Lincoln Co., Maine   I6409 
72 Levensaler, Elizabeth  1 Jul 1769  Waldoboro, Lincoln Co., Maine   I6410 
73 Levensaler, Godfrey  13 May 1769  Waldoboro, Lincoln Co., Maine   I12567 
74 McLellan, Isaac Sr.  15 Sep 1769  Gorham, Cumberland Co., Maine   I3236 
75 Bradbury, Catherine Frothingham  29 Oct 1771  Wiscasset, Lincoln Co., Maine   I6309 
76 Ilsley, Hannah  19 Jan 1771  Portland, Cumberland Co., Maine   I950 
77 Levensaler, Christopher  26 Aug 1771  Waldoboro, Lincoln Co., Maine   I12568 
78 Davis, Mary  15 Sep 1772  Boothbay, Lincoln Co., Maine   I15772 
79 Light, John  10 Aug 1772  Waldoboro, Lincoln Co., Maine   I6421 
80 Decker, Sarah "Sally"  21 Mar 1773  Wiscasset, Lincoln Co., Maine   I3365 
81 Levensaler, Adam  15 Apr 1773  Waldoboro, Lincoln Co., Maine   I56 
82 Levensaler, Elizabeth "Batty"  26 May 1773  Waldoboro, Lincoln Co., Maine   I12569 
83 Turner, Mary K. "Polly"  Abt Sep 1773  Waldoboro, Lincoln Co., Maine   I69 
84 Edwards, Enoch  20 Sep 1774  Cumberland Co., Maine   I1505 
85 McLellan, Nancy  13 Feb 1774  Gorham, Cumberland Co., Maine   I3246 
86 Webster, William  30 Apr 1774  Cape Elizabeth, Cumberland Co., Maine   I13286 
87 Dyer, Peter  25 Dec 1775  Cape Elizabeth, Cumberland Co., Maine   I13298 
88 Levensaler, John  30 Jan 1775  Waldoboro, Lincoln Co., Maine   I6412 
89 Dyer, Simon  2 Mar 1777  Cape Elizabeth, Cumberland Co., Maine   I13308 
90 McLellan, James  15 May 1777  Gorham, Cumberland Co., Maine   I3240 
91 McLellan, Eunice  16 Jun 1778  Gorham, Cumberland Co., Maine   I3247 
92 Stackpole, Hannah  17 Oct 1778  Harpswell, Cumberland Co., Maine   I13287 
93 Edwards, William  2 Sep 1779  Gorham, Cumberland Co., Maine   I1616 
94 McLellan, Abigail  1 Aug 1779  Gorham, Cumberland Co., Maine   I1201 
95 McLellan, Alexander  28 Feb 1780  Gorham, Cumberland Co., Maine   I3249 
96 Adams, Rev. Jonathan  5 Jul 1782  Boothbay, Lincoln Co., Maine   I14183 
97 Turner, Nathaniel  1783  Waldoboro, Lincoln Co., Maine   I11961 
98 McLellan, Samuel  12 Aug 1784  Gorham, Cumberland Co., Maine   I3251 
99 McLellan, Sarah Brown  8 Aug 1785  Gorham, Cumberland Co., Maine   I1494 
100 McLellan, Hon. William  15 Sep 1785  Thomaston, Knox Co., Maine   I70 
101 Harmon, Mehitabel  Abt 1786  Scarborough, Cumberland Co., Maine   I4735 
102 McLellan, David  21 Jun 1786  Cape Elizabeth, Cumberland Co., Maine   I1614 
103 McLellan, Rebecca  11 Dec 1787  Gorham, Cumberland Co., Maine   I12559 
104 Chadburne, Martha  14 Apr 1788  Gorham, Cumberland Co., Maine   I1635 
105 Decker, Mary (Polly)  16 Jan 1788  Kennebec Co., Maine   I6194 
106 McLellan, Sally  22 Jan 1788  Cape Elizabeth, Cumberland Co., Maine   I3254 
107 McLellan, Betsey  7 Nov 1789  Cape Elizabeth, Cumberland Co., Maine   I3255 
108 Clough, Sarah D.  5 Jul 1790  Wiscasset, Lincoln Co., Maine   I2583 
109 Decker, Elizabeth  24 Feb 1791  Kennebec Co., Maine   I6195 
110 Decker, Joshua Jr.  20 May 1791  Buxton, York Co., Maine   I6160 
111 Johnson, Ralph Cross Sr.  Abt 1791  Maine   I1331 
112 McLellan, Thomas  14 Nov 1791  Cape Elizabeth, Cumberland Co., Maine   I3256 
113 Clough, Eliza Lydia St. Barbe  28 Oct 1793  Wiscasset, Lincoln Co., Maine   I71 
114 Decker, Sally  12 Jun 1793  Buxton, York Co., Maine   I6167 
115 McLellan, Capt. Isaac  Abt 1794  Maine   I3261 
116 McLellan, Capt. Simon Jr.  1794  Thomaston, Knox Co., Maine   I3262 
117 Kellogg, Joseph  27 May 1796  Portland, Cumberland Co., Maine   I12666 
118 Levensaler, Sally  Abt 1796  Waldoboro, Lincoln Co., Maine   I12570 
119 Weed, Deborah  5 Oct 1796  Thomaston, Knox Co., Maine   I3390 
120 Clough, Hannah Antoinette  19 Jan 1798  Georgetown, Sagadahoc Co., Maine   I2584 
121 Decker, Asa  4 Sep 1798  Kennebec Co., Maine   I6197 
122 Hobbs, Mrs. Hulda A.  Abt 1798  Maine   I1435 
123 Levensaler, Barden T.  1798  Thomaston, Knox Co., Maine   I3456 
124 Levensaler, Hon. Atwood  8 Nov 1799  Thomaston, Knox Co., Maine   I3457 
125 Brazier, Sophia  6 Oct 1800  Portland, Cumberland Co., Maine   I12667 
126 Edwards, Eunice Edwards  23 Mar 1800  Gorham, Cumberland Co., Maine   I1532 
127 McLellan, Harriet Eliza  15 Jan 1800  Bath, Sagadahoc Co., Maine   I5062 
128 Robinson, Anne James  25 May 1800  Thomaston, Knox Co., Maine   I3556 
129 Edwards, Lathrop Edwards  11 Nov 1801  Otisfield, Cumberland Co., Maine   I1533 
130 Levensaler, Aaron  30 May 1801  Waldoboro, Lincoln Co., Maine   I3200 
131 Levensaler, Lincoln  30 Apr 1801  Thomaston, Knox Co., Maine   I3550 
132 McLellan, James Henry  18 Dec 1801  Bath, Sagadahoc Co., Maine   I5063 
133 Levensaler, Julia S.  25 Oct 1802  Thomaston, Knox Co., Maine   I3551 
134 McLellan, Mary Osgood  15 Aug 1803  Monmouth, Kennebec Co., Maine   I5064 
135 Wheeler, Caroline  1803  Maine   I3370 
136 Edwards, Richard Edwards  30 Mar 1804  Otisfield, Cumberland Co., Maine   I1539 
137 Levensaler, Capt. Caleb  14 Aug 1804  Thomaston, Knox Co., Maine   I3584 
138 Estes, Joseph  3 Feb 1805  Windham, Cumberland Co., Maine   I1631 
139 McLellan, Col. Hugh Davis  24 Jan 1805  Gorham, Cumberland Co., Maine   I1492 
140 McLellan, Rufus  2 Oct 1805  Bath, Sagadahoc Co., Maine   I5962 
141 Edwards, Harriet McLellan  28 Mar 1806  Otisfield, Cumberland Co., Maine   I1540 
142 Levensaler, Leonora  15 Sep 1806  Thomaston, Knox Co., Maine   I54 
143 Gilchrist, Harriet  14 Nov 1807  Camden, Knox Co., Maine   I3585 
144 Kimball, Wilder Bowers  14 Aug 1808  Waterford, Oxford Co., Maine   I1557 
145 Adams, Nancy  16 Dec 1809  Castine, Hancock Co., Maine   I1434 
146 Edwards, Jane McLellan  15 May 1809  Otisfield, Cumberland Co., Maine   I1542 
147 Edwards, Marie E.  8 Jun 1809  Gorham, Cumberland Co., Maine   I1622 
148 Levensaler, Elsie K.  14 Jan 1809  Thomaston, Knox Co., Maine   I3552 
149 McLellan, Charles  4 Feb 1809  Bath, Sagadahoc Co., Maine   I5066 
150 Cutter, Rev. Edward Francis  20 Jan 1810  Portland, Cumberland Co., Maine   I3426 
151 Levensaler, Michal  19 Nov 1810  Thomaston, Knox Co., Maine   I3553 
152 McLellan, Samuel  31 Dec 1810  Bath, Sagadahoc Co., Maine   I5069 
153 Andrews, Mary Johnson  5 Jul 1811  Norway, Oxford Co., Maine   I1644 
154 Edwards, Mary McLellan  23 Mar 1811  Otisfield, Cumberland Co., Maine   I1545 
155 McLellan, Theodore Stone  12 Dec 1811  Gray, Cumberland Co., Maine   I1278 
156 McLellan, William Henry Paine  30 Sep 1811  Warren, Knox Co., Maine   I55 
157 Kellogg, Elijah Jr.  30 May 1813  Portland, Cumberland Co., Maine   I1483 
158 Levensaler, Sarah Ford  17 Dec 1813  Thomaston, Knox Co., Maine   I3554 
159 McLellan, Charles Adams  29 Apr 1813  Milton, Knox Co., Maine   I3372 
160 Edwards, Enoch Edwards  21 Feb 1814  Otisfield, Cumberland Co., Maine   I1546 
161 Edwards, Sargeant Edwards  10 Mar 1815  Otisfield, Cumberland Co., Maine   I1553 
162 McLellan, Mary Eliza  30 Mar 1815  Warren, Knox Co., Maine   I3373 
163 McLellan, Sarah Bowman  10 Dec 1815  Bath, Sagadahoc Co., Maine   I5072 
164 Edwards, James McLellan  5 Dec 1817  Otisfield, Cumberland Co., Maine   I1554 
165 Levensaler, Capt. Orris  17 Jan 1817  Thomaston, Knox Co., Maine   I3555 
166 McLellan, Sarah Washburn  25 Jan 1817  Milton, Knox Co., Maine   I3374 
167 Robinson, Almira  1817  Maine   I1348 
168 McLellan, Louisa Harrington  7 Apr 1818  Bath, Sagadahoc Co., Maine   I5073 
169 Slater, Capt. William  Abt 1819  Maine   I1395 
170 Edwards, Bryce McLellan  22 Aug 1820  Otisfield, Cumberland Co., Maine   I1506 
171 Levensaler, Henry  25 Mar 1820  Waldoboro, Lincoln Co., Maine   I3208 
172 McLellan, George Wingate  1 Dec 1820  Bath, Sagadahoc Co., Maine   I10821 
173 McLellan, Thomas  29 Apr 1821  Maine   I3376 
174 McLellan, Caroline Stead  10 Oct 1822  Bath, Sagadahoc Co., Maine   I5071 
175 McLellan, Charles Adam  22 May 1822  Maine   I1399 
176 Owen, Mary J.  13 Apr 1822  Brunswick, Cumberland Co., Maine   I1292 
177 Edwards, Gen. Clark Swett  26 Mar 1823  Otisfield, Cumberland Co., Maine   I1510 
178 Frost, Miranda  1824  Maine   I1507 
179 McLellan  Apr 1824  Thomaston, Knox Co., Maine   I1449 
180 McLellan, Adeline Dana  5 Aug 1825  Bath, Sagadahoc Co., Maine   I5960 
181 Patterson, Charles M.  3 Dec 1825  Belfast, Waldo Co., Maine   I12010 
182 McLellan, James Brackett  13 Mar 1827  Thomaston, Knox Co., Maine   I3383 
183 Simonton, Sara  Abt 1827  Maine   I1387 
184 McLellan, Lydia Caroline  4 May 1828  Thomaston, Knox Co., Maine   I1451 
185 McLellan, Mary Adams  4 May 1828  Thomaston, Knox Co., Maine   I1450 
186 Margaret  Abt 1829  Maine   I3211 
187 Levensaler, William B.  10 Jun 1829  Thomaston, Knox Co., Maine   I12717 
188 McLellan, Amiah  Abt 1830  Maine   I14332 
189 McLellan, Helen  23 Sep 1830  Warren, Knox Co., Maine   I3380 
190 Edwards, David Andrews  24 Nov 1831  Otisfield, Cumberland Co., Maine   I1645 
191 Levensaler, Dr. Henry Coombs  15 Apr 1831  Thomaston, Knox Co., Maine   I1665 
192 Levensaler, Hester  11 Mar 1831  Thomaston, Knox Co., Maine   I12718 
193 McLellan, Bertha D.  Abt 1831  Thomaston, Knox Co., Maine   I4283 
194 Woodward, Thomas J.  16 Dec 1831  Damariscotta, Lincoln Co., Maine   I3137 
195 Levensaler, Elsie  28 Sep 1832  Thomaston, Knox Co., Maine   I12739 
196 Levensaler, Mary T.  15 Oct 1832  Thomaston, Knox Co., Maine   I12732 
197 McLellan, George Merrill  27 Dec 1832  Maine   I3381 
198 Levensaler, Edward R.  21 Apr 1833  Thomaston, Knox Co., Maine   I12719 
199 McLellan, Adaline Fuller  23 Oct 1833  Thomaston, Knox Co., Maine   I1456 
200 McLellan, Edwin B.  1833  Thomaston, Knox Co., Maine   I6757 
201 Edwards, Dorothy Files  21 Jan 1834  Otisfield, Cumberland Co., Maine   I1650 
202 Levensaler, Olive R.  11 Nov 1834  Thomaston, Knox Co., Maine   I12740 
203 Levensaler, Thomas H.  12 Nov 1834  Thomaston, Knox Co., Maine   I12720 
204 Levensaler, John C.  7 May 1835  Thomaston, Knox Co., Maine   I12733 
205 McLellan, William Thomas  16 Apr 1835  Thomaston, Knox Co., Maine   I1459 
206 Cutter, William McLellan  31 May 1836  Warren, Knox Co., Maine   I6105 
207 Edwards, Albert Marshall  25 Feb 1836  Otisfield, Cumberland Co., Maine   I1651 
208 Levensaler, George D.  13 Dec 1836  Thomaston, Knox Co., Maine   I12722 
209 McLellan, Alden Miller  28 Jan 1836  Warren, Knox Co., Maine   I53 
210 McLellan, Henry K.  8 Oct 1836  Thomaston, Knox Co., Maine   I1460 
211 Estes, Albert Smith  21 Feb 1837  Gorham, Cumberland Co., Maine   I1632 
212 Kimball, George Wilder  3 Apr 1837  Albany Twp., Oxford Co., Maine   I1659 
213 Levensaler, Augusta H.  7 Jan 1837  Thomaston, Knox Co., Maine   I12734 
214 Levensaler, Joseph G.  19 Apr 1837  Thomaston, Knox Co., Maine   I12741 
215 McLellan, Edward Cutter  10 Apr 1837  Maine   I3382 
216 Brown, Brig. Gen. John Marshall  14 Dec 1838  Portland, Cumberland Co., Maine   I10332 
217 Levensaler, Julia F.  28 Oct 1838  Thomaston, Knox Co., Maine   I12723 
218 McLellan, Adelia  1838  Thomaston, Knox Co., Maine   I1474 
219 McLellan, Henry Knox  1 May 1838  Thomaston, Knox Co., Maine   I1463 
220 Edwards, Lt. George William  27 Nov 1839  Gorham, Cumberland Co., Maine   I1568 
221 Levensaler, Adam P.  13 Apr 1839  Thomaston, Knox Co., Maine   I12735 
222 McLellan, Hanna E.  1839  Thomaston, Knox Co., Maine   I1475 
223 McLellan, Sarah Antoinette  19 Aug 1839  Warren, Knox Co., Maine   I63 
224 Curling, Almira C.  Abt 1840  Maine   I6172 
225 Edwards, Isannah Jane  7 Jun 1840  Otisfield, Cumberland Co., Maine   I1656 
226 Estes, Dana  4 Mar 1840  Gorham, Cumberland Co., Maine   I1633 
227 Levensaler, Francis  Abt 1840  Thomaston, Knox Co., Maine   I12724 
228 Levensaler, Atwood J. Jr.  3 Mar 1841  Thomaston, Knox Co., Maine   I3558 
229 Robinson, Horatia Ware  8 Aug 1841  Thomaston, Knox Co., Maine   I6209 
230 Levensaler, Sarah Angelina  6 Apr 1842  Thomaston, Knox Co., Maine   I12725 
231 McLellan, Charles William  8 May 1842  Thomaston, Knox Co., Maine   I65 
232 Johnson, Ralph Cross Jr.  1 Sep 1843  Belfast, Waldo Co., Maine   I972 
233 Levensaler, Charles L.  Abt 1843  Thomaston, Knox Co., Maine   I12726 
234 Levensaler, Orris  Abt 1843  Thomaston, Knox Co., Maine   I12736 
235 Levensaler, Harriet C.  8 Apr 1844  Thomaston, Knox Co., Maine   I12742 
236 Curling, Helen A.  Abt 1845  Maine   I6182 
237 McLellan, William H.  10 May 1845  Gorham, Cumberland Co., Maine   I4733 
238 Levensaler, Nancy I.  12 Jun 1846  Thomaston, Knox Co., Maine   I12737 
239 Levensaler, Thomas J.  18 Jan 1846  Thomaston, Knox Co., Maine   I12729 
240 Levensaler, Catharine  5 Oct 1847  Thomaston, Knox Co., Maine   I12730 
241 McLellan, Atwood  Abt 1847  Maine   I15903 
242 McLellan, Frank Jordan "Franky"  26 Jan 1847  Thomaston, Knox Co., Maine   I3311 
243 Curling, Charles  Abt 1848  Maine   I14324 
244 Cutter, Caroline McLellan  3 Jan 1848  Maine   I6107 
245 Curling, Capt. Frank  21 Jul 1849  South Thomaston, Knox Co., Maine   I14325 
246 Sawtelle, Mary Elizabeth  2 Dec 1849  Maine   I12695 
247 Cushing, Henrietta  30 Oct 1850  Thomaston, Knox Co., Maine   I3557 
248 Levensaler, John West  Abt 1850  Thomaston, Knox Co., Maine   I12731 
249 Levensaler, Lucius C.  8 Jan 1850  Thomaston, Knox Co., Maine   I12738 
250 Levensaler, Raymond  Abt 1850  Thomaston, Knox Co., Maine   I12743 


1 2 Next»


This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, written by Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Genealogy at Pitard.net - created and maintained by D. Pitard Copyright © 2004-2024 All rights reserved. | Data Protection Policy.